-
STARK AND GREENSMITH LIMITED - Unit 6 Charlwood Place, Norwood Hill Road, Horley, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08104300
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 6 Charlwood Place
- Norwood Hill Road
- Horley
- Surrey
- RH6 0EB Unit 6 Charlwood Place, Norwood Hill Road, Horley, Surrey, RH6 0EB UK
Management
- Geschäftsführung
- WEBB-JENKINS, Martine Anne
- WEBB-JENKINS, Matthew John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.06.2012
- Alter der Firma 2012-06-13 11 Jahre
- SIC/NACE
- 64999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Martine Anne Webb-Jenkins
- Mr Matthew John Webb-Jenkins
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- KIRKSTONE CAPITAL LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-25
- Letzte Einreichung: 2023-07-11
-
STARK AND GREENSMITH LIMITED Firmenbeschreibung
- STARK AND GREENSMITH LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08104300. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.06.2012 registriert. STARK AND GREENSMITH LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen KIRKSTONE CAPITAL LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Unit 6 Charlwood Place erreicht werden.
Jetzt sichern STARK AND GREENSMITH LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Stark And Greensmith Limited - Unit 6 Charlwood Place, Norwood Hill Road, Horley, Surrey, Grossbritannien
- 2012-06-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STARK AND GREENSMITH LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
mortgage-satisfy-charge-full (2024-01-11) - MR04
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-03-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-09-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-15) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-03) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-30) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-26) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-31) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-19) - CS01
-
capital-allotment-shares (2018-06-15) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-27) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-27) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-23) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-05-10) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-13) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-07) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-29) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-08-15) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-27) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-24) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-02-21) - MR04
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-08) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-28) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-16) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-allotment-shares (2013-10-02) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-12-07) - AP01
-
incorporation-company (2012-06-13) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2012-06-15) - TM01