-
CAMBRIDGE ONCOMETRIX LIMITED - 3b Homefield Road, Haverhill, Suffolk, CB9 8QP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08101482
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3b Homefield Road
- Haverhill
- Suffolk
- CB9 8QP 3b Homefield Road, Haverhill, Suffolk, CB9 8QP UK
Management
- Geschäftsführung
- ROSSMANN, Maxim
- SOLOVYEV, Dmitry
- SOLTAMOVA SOLOVYEV, Irina
- VONSKII, Maksim
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.06.2012
- Alter der Firma 2012-06-12 12 Jahre
- SIC/NACE
- 72110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Maxim Rossmann
- Mr Dmitry Soloviev
- Mr Maxim Rossmann
- Mr Dmitry Solovyev
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-07-31
- Letzte Einreichung: 2021-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-06-26
- Letzte Einreichung: 2022-06-12
-
CAMBRIDGE ONCOMETRIX LIMITED Firmenbeschreibung
- CAMBRIDGE ONCOMETRIX LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08101482. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.06.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "72110" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 3B Homefield Road erreicht werden.
Jetzt sichern CAMBRIDGE ONCOMETRIX LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cambridge Oncometrix Limited - 3b Homefield Road, Haverhill, Suffolk, CB9 8QP, Grossbritannien
- 2012-06-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CAMBRIDGE ONCOMETRIX LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-03-30) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-03-31) - DISS40
keyboard_arrow_right 2022
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2022-06-29) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-29) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2022-09-27) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2022-10-12) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2021
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-03-31) - PSC04
-
gazette-notice-compulsory (2021-11-30) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-22) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-31) - CH01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-12-01) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-11-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-23) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-12-23) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-10-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-29) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-29) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-03) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-06-03) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-06-30) - AA
-
capital-allotment-shares (2019-07-11) - SH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-05-02) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-06-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-30) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-07) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-12-12) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-12-06) - SH01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-08) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-03-03) - AA01
-
termination-director-company-with-name (2014-03-01) - TM01
-
capital-allotment-shares (2014-02-21) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-08) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-08) - AP01
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-01-08) - SH02
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-06-12) - NEWINC