-
KEMBLE DEVELOPMENTS LIMITED - Sigeric Business Park, Holme Lacy Road, Hereford, HR2 6BQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08100417
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Sigeric Business Park
- Holme Lacy Road
- Hereford
- HR2 6BQ Sigeric Business Park, Holme Lacy Road, Hereford, HR2 6BQ UK
Management
- Geschäftsführung
- KING, Peter Graham
- VELDHUIS, Tinka Madelon
- KING, Dominic Neville
- Prokuristen
- KING, Michael John Cape
- KING, Sharon
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.06.2012
- Alter der Firma 2012-06-11 11 Jahre
- SIC/NACE
- 88100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Peter Graham King
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-06-11
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-12
- Letzte Einreichung: 2023-09-28
-
KEMBLE DEVELOPMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- KEMBLE DEVELOPMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08100417. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.06.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "88100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 2 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.06.2013.Die Firma kann schriftlich über Sigeric Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern KEMBLE DEVELOPMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Kemble Developments Limited - Sigeric Business Park, Holme Lacy Road, Hereford, HR2 6BQ, Grossbritannien
- 2012-06-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KEMBLE DEVELOPMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
memorandum-articles (2023-10-09) - MA
-
resolution (2023-10-09) - RESOLUTIONS
-
resolution (2023-03-09) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2023-05-02) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-10-03) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2023-10-03) - AP03
-
capital-name-of-class-of-shares (2023-10-09) - SH08
-
memorandum-articles (2023-03-09) - MA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-03-06) - AA
-
capital-allotment-shares (2023-03-03) - SH01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2021-05-06) - SH02
-
confirmation-statement-with-updates (2021-10-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-07-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-11) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-05-02) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-06-07) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-16) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-14) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-11) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-13) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-31) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-07-24) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-28) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-06-26) - SH01
-
resolution (2013-01-16) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-06-11) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2012-10-23) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-06-20) - AP01