-
GNERGY HOLDINGS LIMITED - Suite 3 91 Mayflower Street, Plymouth, PL1 1SB, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08073492
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 3 91 Mayflower Street
- Plymouth
- PL1 1SB
- England Suite 3 91 Mayflower Street, Plymouth, PL1 1SB, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DEWAN, Tikendra Dal
- RAI, Chhatra Bahadur
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.05.2012
- Gelöscht am:
- 2021-06-01
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- GNERGY LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-30
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-05-31
- Letzte Einreichung: 2020-05-17
-
GNERGY HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- GNERGY HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08073492. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 17.05.2012 registriert. GNERGY HOLDINGS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GNERGY LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Suite 3 91 Mayflower Street erreicht werden.
Jetzt sichern GNERGY HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Gnergy Holdings Limited - Suite 3 91 Mayflower Street, Plymouth, PL1 1SB, England, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GNERGY HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-notice-voluntary (2021-03-16) - GAZ1(A)
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-04) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-04) - CH01
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-03-04) - DS01
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-17) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-27) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-05-27) - TM02
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-12-30) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-04-23) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-07-04) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-16) - AA
-
resolution (2018-08-28) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-11) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-14) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-08-19) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-16) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-08-15) - CH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-08-14) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-08-11) - PSC08
-
gazette-notice-compulsory (2017-08-08) - GAZ1
-
capital-alter-shares-subdivision (2017-04-29) - SH02
-
resolution (2017-04-26) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2017-04-29) - SH01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-27) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-04-05) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-06) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-15) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-03-21) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-19) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-03-19) - AP03
-
change-of-name-notice (2013-05-28) - CONNOT
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-04) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-03) - AD01
-
capital-allotment-shares (2013-06-07) - SH01
-
certificate-change-of-name-company (2013-06-25) - CERTNM
-
resolution (2013-05-28) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-10-29) - AD01
-
incorporation-company (2012-05-17) - NEWINC