-
TEDIPAY (UK) LTD - Beaver House, 23-38 Hythe Bridge Street, Oxford, OX1 2EP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08061624
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Beaver House
- 23-38 Hythe Bridge Street
- Oxford
- OX1 2EP Beaver House, 23-38 Hythe Bridge Street, Oxford, OX1 2EP UK
Management
- Geschäftsführung
- ACKLAM, Jeremy Charles
- BUNTING, Paul Joseph
- PENINGTON, Michael Geoffrey
- SHOOTER, Adrian
- TOMLIN, Alan Colin
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.05.2012
- Gelöscht am:
- 2020-06-19
- SIC/NACE
- 27900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Global Travel Ventures Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-02-15
- Letzte Einreichung: 2018-02-01
-
TEDIPAY (UK) LTD Firmenbeschreibung
- TEDIPAY (UK) LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08061624. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 09.05.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "27900" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Beaver House erreicht werden.
Jetzt sichern TEDIPAY (UK) LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Tedipay (Uk) Ltd - Beaver House, 23-38 Hythe Bridge Street, Oxford, OX1 2EP, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TEDIPAY (UK) LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-06-19) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2020-03-05) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-03-19) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-11) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-02-08) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-02-08) - 600
-
resolution (2019-02-08) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-04-19) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-12) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-16) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-10) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-02-20) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-09) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-12) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-02-21) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-07) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-22) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-10-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-12) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-21) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-10-20) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-24) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-09-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-30) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-10-12) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-05) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-02-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-12-12) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-27) - AR01
-
capital-allotment-shares (2014-11-25) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-11-25) - SH02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-12-12) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-12) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-02-08) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-15) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-24) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-05-09) - NEWINC