-
79 GREAT SUFFOLK STREET LIMITED - First Floor Audit House, 151 High Street, Billericay, CM12 9AB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08061352
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- First Floor Audit House
- 151 High Street
- Billericay
- CM12 9AB
- England First Floor Audit House, 151 High Street, Billericay, CM12 9AB, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BOYD, Ian James
- FRANKLIN, Luke Michael
- Prokuristen
- VESTRA PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.05.2012
- Alter der Firma 2012-05-09 12 Jahre
- SIC/NACE
- 98000
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Ian James Boyd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-02-28
- Letzte Einreichung: 2020-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-12
- Letzte Einreichung: 2019-12-01
-
79 GREAT SUFFOLK STREET LIMITED Firmenbeschreibung
- 79 GREAT SUFFOLK STREET LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08061352. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.05.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "98000" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über First Floor Audit House erreicht werden.
Jetzt sichern 79 GREAT SUFFOLK STREET LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 79 Great Suffolk Street Limited - First Floor Audit House, 151 High Street, Billericay, CM12 9AB, Grossbritannien
- 2012-05-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 79 GREAT SUFFOLK STREET LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-07-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-14) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-17) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-07-30) - AA
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2019-03-22) - AP04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-22) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-02-28) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-02-26) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-notice-compulsory (2018-05-01) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-17) - AD01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2018-05-17) - AP04
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-05-23) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-05-26) - DISS40
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-05-17) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-13) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-23) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-06-01) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-31) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2016-05-03) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-16) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-03-16) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-09) - AA
-
resolution (2015-04-23) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-24) - AR01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2015-03-16) - AP04
keyboard_arrow_right 2014
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-10-04) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-02) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2014-09-09) - GAZ1
-
capital-allotment-shares (2014-03-13) - SH01
-
resolution (2014-03-10) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-08) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-05-09) - NEWINC