-
LAKESHORE LENDING LIMITED - 2nd Floor 110 Cannon Street, London, EC4N 6EU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08057825
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2nd Floor 110 Cannon Street
- London
- EC4N 6EU 2nd Floor 110 Cannon Street, London, EC4N 6EU UK
Management
- Geschäftsführung
- SHEPHERD, Edward Michael
- WEISS, Jeff
- WEISS, Zev
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.05.2012
- Alter der Firma 2012-05-04 12 Jahre
- SIC/NACE
- 47789
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-10-31
- Letzte Einreichung: 2018-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-05-04
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-05-18
- Letzte Einreichung: 2019-05-04
-
LAKESHORE LENDING LIMITED Firmenbeschreibung
- LAKESHORE LENDING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08057825. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.05.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47789" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 04.05.2013.Die Firma kann schriftlich über 2Nd Floor 110 Cannon Street erreicht werden.
Jetzt sichern LAKESHORE LENDING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Lakeshore Lending Limited - 2nd Floor 110 Cannon Street, London, EC4N 6EU, Grossbritannien
- 2012-05-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LAKESHORE LENDING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-12-17) - LIQ03
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-07-05) - MR04
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-11-28) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-11-23) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-11-23) - 600
-
resolution (2020-11-10) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-02-02) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2019-01-08) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-02-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-08) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-04-12) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-12) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-12-10) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-17) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-11) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-05-03) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-18) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-17) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-12-05) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-11-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-01-10) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-02-25) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-17) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-03-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-12) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-05) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-05) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-07-29) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2013-07-29) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-27) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-08-19) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-12-03) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-08-22) - AA01
-
incorporation-company (2012-05-04) - NEWINC