-
PB LEASING AIRCRAFT NO.28 (UK) LTD - Haslers, Old Station Road, Loughton, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08045335
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Haslers
- Old Station Road
- Loughton
- Essex
- IG10 4PL Haslers, Old Station Road, Loughton, Essex, IG10 4PL UK
Management
- Geschäftsführung
- RASAMNY, Ramzy Fouad
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.04.2012
- Gelöscht am:
- 2021-07-08
- SIC/NACE
- 77351
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Ramzy Fouad Rasamny
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-08-23
- Letzte Einreichung: 2018-08-09
-
PB LEASING AIRCRAFT NO.28 (UK) LTD Firmenbeschreibung
- PB LEASING AIRCRAFT NO.28 (UK) LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08045335. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 25.04.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "77351" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Haslers erreicht werden.
Jetzt sichern PB LEASING AIRCRAFT NO.28 (UK) LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pb Leasing Aircraft No.28 (Uk) Ltd - Haslers, Old Station Road, Loughton, Essex, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PB LEASING AIRCRAFT NO.28 (UK) LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-08-11) - LIQ03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-02) - TM01
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2020-02-14) - LIQ10
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-07-01) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-06-18) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-06-18) - 600
-
resolution (2019-06-18) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-19) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-22) - TM01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-07-09) - 600
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-19) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-16) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-01-16) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-03-14) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-16) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-09) - CS01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-31) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-31) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-29) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-04-29) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-08) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-11-05) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-24) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-08-24) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2013-08-20) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-04-25) - NEWINC