-
G & M SAFE DECK LIMITED - The Glades Festival Way, Festival Park, Stoke On Trent, Staffordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08036213
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Glades Festival Way
- Festival Park
- Stoke On Trent
- Staffordshire
- ST1 5SQ
- United Kingdom The Glades Festival Way, Festival Park, Stoke On Trent, Staffordshire, ST1 5SQ, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- PICKLES, Jayne
- PICKLES, Mark Anthony
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.04.2012
- Alter der Firma 2012-04-18 12 Jahre
- SIC/NACE
- 32990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Mark Pickles
- Mr Mark Anthony Pickles
- -
- G&M Group Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-10-31
- Letzte Einreichung: 2023-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-09-15
- Letzte Einreichung: 2023-09-01
-
G & M SAFE DECK LIMITED Firmenbeschreibung
- G & M SAFE DECK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08036213. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.04.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "32990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über The Glades Festival Way erreicht werden.
Jetzt sichern G & M SAFE DECK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: G & M Safe Deck Limited - The Glades Festival Way, Festival Park, Stoke On Trent, Staffordshire, Grossbritannien
- 2012-04-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu G & M SAFE DECK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-01-04) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-03-01) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-05-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-09-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-01-04) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-01-04) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2022-01-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-08) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-12-01) - MR01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-09-22) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-07-29) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-25) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-06) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-11-29) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-11-14) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-10) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-11-29) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-28) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-03-06) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-18) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-21) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-29) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-08-10) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-03) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-12-24) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-06-20) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-22) - AR01
-
incorporation-company (2012-04-18) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-04-30) - AA01