-
PURE CRAFT BARS LIMITED - The Brewery Spernall Lane, Great Alne, Alcester, B49 6JF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08022243
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Brewery Spernall Lane
- Great Alne
- Alcester
- B49 6JF
- England The Brewery Spernall Lane, Great Alne, Alcester, B49 6JF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HALSEY, Paul
- HUNT, John Andrew
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.04.2012
- Alter der Firma 2012-04-05 12 Jahre
- SIC/NACE
- 56302
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- In Administration
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-05-31
- Letzte Einreichung: 2022-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-05
- Letzte Einreichung: 2023-07-22
-
PURE CRAFT BARS LIMITED Firmenbeschreibung
- PURE CRAFT BARS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08022243. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.04.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56302" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über The Brewery Spernall Lane erreicht werden.
Jetzt sichern PURE CRAFT BARS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pure Craft Bars Limited - The Brewery Spernall Lane, Great Alne, Alcester, B49 6JF, Grossbritannien
- 2012-04-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PURE CRAFT BARS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2024-01-03) - AM01
keyboard_arrow_right 2023
-
legacy (2023-06-12) - GUARANTEE2
-
legacy (2023-06-12) - PARENT_ACC
-
legacy (2023-06-22) - AGREEMENT2
-
legacy (2023-06-22) - GUARANTEE2
-
legacy (2023-06-22) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-06-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-07-31) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-09-01) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-12-15) - MR04
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-02-04) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-09-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-17) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-11-16) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-09) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2020-11-10) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-10) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-11-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-06-25) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-28) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-06-06) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-06-06) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-11) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-25) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-21) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-08) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-12-12) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-11) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-11) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-11) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-04-11) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-11) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-02) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-12-12) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-04-11) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
resolution (2013-07-18) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-07-09) - SH02
-
capital-allotment-shares (2013-07-04) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-25) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-06-25) - SH01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-04-05) - NEWINC