-
SIGNATURE HOLIDAYS LIMITED - Hpb House, 24-28 Old Station Road, Newmarket, Suffolk, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08020630
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Hpb House
- 24-28 Old Station Road
- Newmarket
- Suffolk
- CB8 8EH Hpb House, 24-28 Old Station Road, Newmarket, Suffolk, CB8 8EH UK
Management
- Geschäftsführung
- BABER, Geoffrey Donald
- BOYCE, James Christopher
- BOYCE, Robert Gerald
- Prokuristen
- BABER, Geoffrey Donald
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.04.2012
- Alter der Firma 2012-04-04 12 Jahre
- SIC/NACE
- 68320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Geoffrey Donald Baber
- Mr Robert Gerald Boyce
- Mr James Christopher Boyce
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SYLVAN HOLIDAYS LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 549300D51QW1Q0S0JR33
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-18
- Letzte Einreichung: 2021-04-04
-
SIGNATURE HOLIDAYS LIMITED Firmenbeschreibung
- SIGNATURE HOLIDAYS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08020630. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.04.2012 registriert. SIGNATURE HOLIDAYS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SYLVAN HOLIDAYS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68320" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Hpb House erreicht werden.
Jetzt sichern SIGNATURE HOLIDAYS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Signature Holidays Limited - Hpb House, 24-28 Old Station Road, Newmarket, Suffolk, Grossbritannien
- 2012-04-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SIGNATURE HOLIDAYS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-12-30) - AA
-
resolution (2020-01-15) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-15) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-06-12) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-11-26) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-02) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-07) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-06-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-12-31) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-12-31) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-06-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-09-13) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-06-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-05-17) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-06-22) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-17) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-14) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-04-08) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-03-22) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-10) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-04-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-05-07) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-11) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-04) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-15) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-04-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-08) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-11) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-01-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-04-04) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-05-22) - AA01
-
change-of-name-notice (2012-12-11) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2012-12-11) - CERTNM