-
A T CONTRACTING & PLANT HIRE LTD - Colinton House, Leicester Road, Bedworth, Warwickshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08003365
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Colinton House
- Leicester Road
- Bedworth
- Warwickshire
- CV12 8AB Colinton House, Leicester Road, Bedworth, Warwickshire, CV12 8AB UK
Management
- Geschäftsführung
- BRAILSFORD, David
- TAYLOR, Carly
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.03.2012
- Alter der Firma 2012-03-23 12 Jahre
- SIC/NACE
- 43120
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr David Brailsford
- Mrs Carly Taylor
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- AT PLANT SALES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-06
- Letzte Einreichung: 2020-07-23
-
A T CONTRACTING & PLANT HIRE LTD Firmenbeschreibung
- A T CONTRACTING & PLANT HIRE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08003365. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.03.2012 registriert. A T CONTRACTING & PLANT HIRE LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen AT PLANT SALES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43120" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Colinton House erreicht werden.
Jetzt sichern A T CONTRACTING & PLANT HIRE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: A T Contracting & Plant Hire Ltd - Colinton House, Leicester Road, Bedworth, Warwickshire, Grossbritannien
- 2012-03-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu A T CONTRACTING & PLANT HIRE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-09-17) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-04-22) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-16) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-04-16) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-06-12) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-24) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-09-17) - PSC01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-06-14) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-01-16) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-06-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-04-20) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-20) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-11-09) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-04-18) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-22) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-01-05) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-30) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
certificate-change-of-name-company (2014-08-31) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2014-08-31) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-07-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-17) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-12) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-03-12) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-03-23) - NEWINC