-
VANDERMOLEN FILM CO. LTD - Evergreen House North Grafton Place, Euston, London, NW1 2DX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07994036
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Evergreen House North Grafton Place
- Euston
- London
- NW1 2DX Evergreen House North Grafton Place, Euston, London, NW1 2DX UK
Management
- Geschäftsführung
- VANDERMOLEN, Lee
- VANDERMOLEN, Nadine Laure
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.03.2012
- Alter der Firma 2012-03-16 12 Jahre
- SIC/NACE
- 59120
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Nadine Laure Vandermolen
- Mr Lee Vandermolen
- Mr Lee Vandermolen
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-16
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-27
- Letzte Einreichung: 2020-03-16
-
VANDERMOLEN FILM CO. LTD Firmenbeschreibung
- VANDERMOLEN FILM CO. LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07994036. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.03.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "59120" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.03.2013.Die Firma kann schriftlich über Evergreen House North Grafton Place erreicht werden.
Jetzt sichern VANDERMOLEN FILM CO. LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Vandermolen Film Co. Ltd - Evergreen House North Grafton Place, Euston, London, NW1 2DX, Grossbritannien
- 2012-03-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VANDERMOLEN FILM CO. LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2023-10-02) - WU07
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2022-07-28) - WU07
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2021-09-08) - WU07
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-16) - CS01
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2020-04-20) - COCOMP
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-09-19) - AD01
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2020-09-30) - WU04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-10-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-11-29) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-26) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-04-23) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-17) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-05) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-04) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-07) - MR01
-
capital-allotment-shares (2015-12-09) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-16) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-22) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-03) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-29) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-06-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-06-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-03-16) - NEWINC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-05-18) - AD01