-
MC 497 LIMITED - 30, St. Pauls Square, Birmingham, West Midlands, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07987350
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 30
- St. Pauls Square
- Birmingham
- West Midlands
- B3 1QZ 30, St. Pauls Square, Birmingham, West Midlands, B3 1QZ UK
Management
- Geschäftsführung
- BARRASS, David John
- HALL, Dennis John
- KING, Andrew Mark
- NORMAN, David Howard
- Prokuristen
- KING, Andrew Mark
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.03.2012
- Gelöscht am:
- 2020-05-21
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Bcpe Ii General Partner Llp
- Technology Growth (Gp) Llp
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- SGX SENSORTECH LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-03-31
- Letzte Einreichung: 2016-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2015-03-12
-
MC 497 LIMITED Firmenbeschreibung
- MC 497 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07987350. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 12.03.2012 registriert. MC 497 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SGX SENSORTECH LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2014 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 12.03.2015.Die Firma kann schriftlich über 30 erreicht werden.
Jetzt sichern MC 497 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mc 497 Limited - 30, St. Pauls Square, Birmingham, West Midlands, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MC 497 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-05-21) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2020-02-21) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-03-13) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-02-22) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-12) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2018-02-09) - LIQ01
-
resolution (2018-02-09) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-29) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-01-20) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-09) - AP01
-
capital-allotment-shares (2017-01-22) - SH01
-
resolution (2017-01-23) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-04-03) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-10-19) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
memorandum-articles (2016-12-29) - MA
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-12-20) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2016-12-20) - SH10
-
resolution (2016-11-17) - RESOLUTIONS
-
resolution (2016-11-09) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2016-10-18) - CONNOT
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-01-08) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-12-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-19) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-03-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-10-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-04-18) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-04-18) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2012-04-18) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2012-05-16) - CERTNM
-
legacy (2012-05-23) - MG01
-
capital-allotment-shares (2012-05-28) - SH01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-05-28) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-05-28) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-12-17) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-12-18) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2012-12-18) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2012-12-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-05-28) - AP01
-
incorporation-company (2012-03-12) - NEWINC