-
UNIPART ACCELERATED LOGISTICS LIMITED - Unipart House Garsington Road, Cowley, Oxford, Oxfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07983082
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unipart House Garsington Road
- Cowley
- Oxford
- Oxfordshire
- OX4 2PG Unipart House Garsington Road, Cowley, Oxford, Oxfordshire, OX4 2PG UK
Management
- Geschäftsführung
- LEIGH, Darren Peter
- LEUNG, Alex Raymond
- WELDON, Christopher James
- Prokuristen
- RUSSELL, Tanya
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.03.2012
- Alter der Firma 2012-03-09 12 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Unipart Logistics Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-09
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-02-15
- Letzte Einreichung: 2023-02-01
-
UNIPART ACCELERATED LOGISTICS LIMITED Firmenbeschreibung
- UNIPART ACCELERATED LOGISTICS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07983082. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.03.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.03.2013.Die Firma kann schriftlich über Unipart House Garsington Road erreicht werden.
Jetzt sichern UNIPART ACCELERATED LOGISTICS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Unipart Accelerated Logistics Limited - Unipart House Garsington Road, Cowley, Oxford, Oxfordshire, Grossbritannien
- 2012-03-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu UNIPART ACCELERATED LOGISTICS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-01) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-03-20) - MR04
keyboard_arrow_right 2022
-
auditors-resignation-company (2022-01-21) - AUD
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-09-21) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-11-18) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-09-16) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-08-12) - TM02
-
memorandum-articles (2021-05-10) - MA
-
resolution (2021-05-10) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-08) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-03-19) - MR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2021-09-17) - AP03
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-04-16) - MR01
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-05-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-06) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-09-22) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-01-16) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-15) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-15) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-08-22) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2019-12-19) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-09-27) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-06-25) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-19) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-05) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-27) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-18) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-11-11) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-10-04) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-08) - MR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-06-10) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-09) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-06-10) - AP03
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-09-30) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-31) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-10-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-11-01) - MG01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-05-03) - AA01
-
incorporation-company (2012-03-09) - NEWINC