-
JASON ATHERTON RESTAURANT CONSULTANCY LIMITED - 13 Pollen Street, London, W1S 1NH, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07982782
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 13 Pollen Street
- London
- W1S 1NH
- England 13 Pollen Street, London, W1S 1NH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ATHERTON, Irha Sheryll Bacera
- ATHERTON, Jason
- TAPLOW HOUSE HOTEL LTD
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.03.2012
- Alter der Firma 2012-03-08 12 Jahre
- SIC/NACE
- 56101
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Jason Atherton
- Mr Jason Atherton
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-01-31
- Letzte Einreichung: 2021-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-08
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-03-22
- Letzte Einreichung: 2022-03-08
-
JASON ATHERTON RESTAURANT CONSULTANCY LIMITED Firmenbeschreibung
- JASON ATHERTON RESTAURANT CONSULTANCY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07982782. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.03.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56101" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 08.03.2013.Die Firma kann schriftlich über 13 Pollen Street erreicht werden.
Jetzt sichern JASON ATHERTON RESTAURANT CONSULTANCY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jason Atherton Restaurant Consultancy Limited - 13 Pollen Street, London, W1S 1NH, England, Grossbritannien
- 2012-03-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JASON ATHERTON RESTAURANT CONSULTANCY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-01-31) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-04-04) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-04-04) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-04-05) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-01-31) - TM02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-31) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-06-25) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-22) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-10) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-21) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-01) - TM01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2016-03-01) - AP02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-27) - AA
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2016-02-11) - AP02
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-04-21) - CH03
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-17) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-21) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-04-21) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-21) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-05) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-06) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-09-04) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-03) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-01-16) - AP03
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-03-08) - NEWINC