-
EMERGENCY SITE SERVICES LTD - 32 Moreland Avenue, Colnbrook, Slough, SL3 0LR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07980076
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 32 Moreland Avenue
- Colnbrook
- Slough
- SL3 0LR
- United Kingdom 32 Moreland Avenue, Colnbrook, Slough, SL3 0LR, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- HUGHES, Daniel
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.03.2012
- Alter der Firma 2012-03-07 12 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Daniel Hughes
- -
- Mr Daniel Hughes
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- H MCGOVERN & SON EMERGENCY SITE SERVICES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2017-08-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-02-04
- Letzte Einreichung: 2019-01-21
-
EMERGENCY SITE SERVICES LTD Firmenbeschreibung
- EMERGENCY SITE SERVICES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07980076. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.03.2012 registriert. EMERGENCY SITE SERVICES LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen H MCGOVERN & SON EMERGENCY SITE SERVICES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 28.08.2017.Die Firma kann schriftlich über 32 Moreland Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern EMERGENCY SITE SERVICES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Emergency Site Services Ltd - 32 Moreland Avenue, Colnbrook, Slough, SL3 0LR, Grossbritannien
- 2012-03-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EMERGENCY SITE SERVICES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-compulsory (2020-04-14) - GAZ1
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-01-23) - PSC07
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-01-23) - TM02
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-29) - AAMD
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-12-30) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-11-20) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2019-11-19) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-26) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-28) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-08) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-04-19) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-06-22) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-21) - AR01
-
change-of-name-notice (2015-05-23) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2015-06-08) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-13) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-13) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-13) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-15) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-19) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-08-28) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-28) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-04) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-03-07) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2012-04-27) - TM01
-
capital-allotment-shares (2012-04-27) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-04-27) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-08-01) - AD01