-
RCOG EQUIPMENT RENTAL LIMITED - 112 Jermyn Street Jermyn Street, London, SW1Y 6LS, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07978023
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 112 Jermyn Street Jermyn Street
- London
- SW1Y 6LS
- England 112 Jermyn Street Jermyn Street, London, SW1Y 6LS, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ROCHOLL, Patrick Horst
- WHITE, Giles Alistair
- Prokuristen
- ROCHOLL, Patrick Horst
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.03.2012
- Alter der Firma 2012-03-06 12 Jahre
- SIC/NACE
- 77390
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Rcog Tank Leasing Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- GEM CONTAINERS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-14
- Letzte Einreichung: 2021-02-28
-
RCOG EQUIPMENT RENTAL LIMITED Firmenbeschreibung
- RCOG EQUIPMENT RENTAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07978023. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.03.2012 registriert. RCOG EQUIPMENT RENTAL LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GEM CONTAINERS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "77390" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 112 Jermyn Street Jermyn Street erreicht werden.
Jetzt sichern RCOG EQUIPMENT RENTAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rcog Equipment Rental Limited - 112 Jermyn Street Jermyn Street, London, SW1Y 6LS, England, Grossbritannien
- 2012-03-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RCOG EQUIPMENT RENTAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-05-19) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-06) - CS01
-
resolution (2021-06-11) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-05-12) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-10-03) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-10-04) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-10-07) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charles-court-order-extend-with-charge-number-charge-creation-date (2019-12-24) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-01-04) - CH01
-
capital-allotment-shares (2017-02-17) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-28) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-15) - MR01
-
resolution (2017-08-22) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-23) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-12-23) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-23) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-12-23) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-04) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-10) - TM01
-
capital-allotment-shares (2016-04-04) - SH01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-30) - AA
-
capital-allotment-shares (2014-09-23) - SH01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-07-16) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2014-07-15) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-allotment-shares (2013-06-21) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-06-24) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-24) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-07-19) - SH01
-
resolution (2013-07-24) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-07) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-06-24) - CH03
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-10-09) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-14) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-03-09) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-03-06) - AA01
-
incorporation-company (2012-03-06) - NEWINC