-
FULL MOON (MAYFAIR) LIMITED - 22 Woodstock Street, London, W1C 2AR, United Kingdom, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07976962
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 22 Woodstock Street
- London
- W1C 2AR
- United Kingdom 22 Woodstock Street, London, W1C 2AR, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BIN ABDUL RAHIM, Rezal
- ONG, Eng Leong
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.03.2012
- Gelöscht am:
- 2021-09-07
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Hrh Hrh Crown Prince Ismail Ibrahim
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-30
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-29
- Letzte Einreichung: 2021-01-15
-
FULL MOON (MAYFAIR) LIMITED Firmenbeschreibung
- FULL MOON (MAYFAIR) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07976962. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.03.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.03.2013.Die Firma kann schriftlich über 22 Woodstock Street erreicht werden.
Jetzt sichern FULL MOON (MAYFAIR) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Full Moon (Mayfair) Limited - 22 Woodstock Street, London, W1C 2AR, United Kingdom, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FULL MOON (MAYFAIR) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-06-14) - DS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-18) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-02-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2020-08-07) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-30) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-27) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-20) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-04) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-03-30) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-27) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-03-05) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-05) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-03-01) - PSC09
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-01) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-03-07) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-26) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2018-03-06) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-13) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-03-15) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2017-03-14) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-12-11) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-08) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-31) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-08) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-16) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-01-16) - MR04
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-03-14) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-22) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-07-19) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-26) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-06) - MR01
-
termination-director-company-with-name (2013-11-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-26) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-12-05) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-05-10) - AP01
-
legacy (2012-05-03) - MG01
-
capital-allotment-shares (2012-04-04) - SH01
-
incorporation-company (2012-03-06) - NEWINC