-
GYSBP (NEXUS) LIMITED - Priory Centre, Priory Plain, Great Yarmouth, NR30 1NW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07970563
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Priory Centre
- Priory Plain
- Great Yarmouth
- NR30 1NW
- England Priory Centre, Priory Plain, Great Yarmouth, NR30 1NW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DENBY, George William
- ELKERTON, Carol Ann
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.02.2012
- Gelöscht am:
- 2021-04-06
- SIC/NACE
- 85320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Great Yarmouth Schools And Business Partnership
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-03-14
- Letzte Einreichung: 2019-02-28
-
GYSBP (NEXUS) LIMITED Firmenbeschreibung
- GYSBP (NEXUS) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07970563. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 29.02.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "85320" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 28.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Priory Centre erreicht werden.
Jetzt sichern GYSBP (NEXUS) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Gysbp (Nexus) Limited - Priory Centre, Priory Plain, Great Yarmouth, NR30 1NW, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GYSBP (NEXUS) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-02-06) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2021-01-12) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-05) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-06) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-06) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-22) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-09-18) - AA01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-05-14) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-08) - PSC02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-07) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-15) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-15) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-02-03) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-01-11) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2017-01-03) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-01-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-22) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-26) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-05) - AR01
-
accounts-amended-with-accounts-type-full (2015-01-06) - AAMD
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-01) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-07-15) - AA01
-
termination-director-company-with-name (2014-07-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-29) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-25) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-08) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-29) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-15) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-03) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-08-02) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-04-17) - AP01
-
incorporation-company (2012-02-29) - NEWINC