-
PREMIER CABLES HOLDINGS LIMITED - 11 Humphrys Road, Dunstable, LU5 4TP, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07970241
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 11 Humphrys Road
- Dunstable
- LU5 4TP
- England 11 Humphrys Road, Dunstable, LU5 4TP, England UK
Management
- Geschäftsführung
- SHAHIN, Zainon Eid John
- TESKE, Timothy James
- VEUM, Michael Paul
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.02.2012
- Alter der Firma 2012-02-29 12 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Iewc Uk & Ireland Ltd
- Premier Cables Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-11
- Letzte Einreichung: 2020-02-29
-
PREMIER CABLES HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- PREMIER CABLES HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07970241. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.02.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 11 Humphrys Road erreicht werden.
Jetzt sichern PREMIER CABLES HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Premier Cables Holdings Limited - 11 Humphrys Road, Dunstable, LU5 4TP, England, Grossbritannien
- 2012-02-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PREMIER CABLES HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-03-22) - PSC05
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-03-01) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-02-09) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-01) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-03-18) - MR04
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2020-11-04) - MR05
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-10-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-10-04) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-18) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-02) - AP01
-
resolution (2018-02-05) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-13) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-19) - CS01
-
memorandum-articles (2018-04-11) - MA
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-06) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-02) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-04-26) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-08-01) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-11) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-10-05) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-26) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-29) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-02-23) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-14) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-01-07) - MR04
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-04-14) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-31) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-31) - AP01
-
auditors-resignation-company (2015-10-05) - AUD
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-31) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-group (2014-05-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-11) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-03-11) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-group (2013-09-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-05-18) - AA01
-
incorporation-company (2012-02-29) - NEWINC
-
legacy (2012-06-07) - MG01
-
change-sail-address-company (2012-05-18) - AD02
-
capital-allotment-shares (2012-09-19) - SH01