-
RBK MECHANICAL LTD - KINGSBRIDGE CORPORATE SOLUTIONS, 1st Floor Lowgate House, Lowgate, Hull, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07969358
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- KINGSBRIDGE CORPORATE SOLUTIONS
- 1st Floor Lowgate House
- Lowgate
- Hull
- HU1 1EL KINGSBRIDGE CORPORATE SOLUTIONS, 1st Floor Lowgate House, Lowgate, Hull, HU1 1EL UK
Management
- Geschäftsführung
- CUMISKEY, Alex Andrew
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.02.2012
- Gelöscht am:
- 2020-07-30
- SIC/NACE
- 43220
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-11-30
- Letzte Einreichung: 2015-02-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2015-10-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-10-21
- Letzte Einreichung:
-
RBK MECHANICAL LTD Firmenbeschreibung
- RBK MECHANICAL LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07969358. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 29.02.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43220" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 28.02.2015 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.10.2015.Die Firma kann schriftlich über Kingsbridge Corporate Solutions erreicht werden.
Jetzt sichern RBK MECHANICAL LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rbk Mechanical Ltd - KINGSBRIDGE CORPORATE SOLUTIONS, 1st Floor Lowgate House, Lowgate, Hull, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RBK MECHANICAL LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-04-30) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-08-29) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-08-24) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-07-05) - 600
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2017-06-21) - AM22
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2017-04-12) - 2.16B
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2017-02-08) - 2.24B
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2016-09-23) - 2.23B
-
liquidation-in-administration-proposals (2016-09-02) - 2.17B
-
liquidation-voluntary-arrangement-completion (2016-07-21) - 1.4
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-18) - AD01
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2016-02-09) - 1.1
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-02-01) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-20) - MR01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2016-07-29) - 2.12B
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-07) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-19) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-01) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-22) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-18) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-04-02) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-21) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-11) - AA
-
legacy (2013-03-14) - MG01
-
termination-director-company-with-name (2013-07-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-12) - AP01
-
capital-allotment-shares (2013-07-22) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-23) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-11-14) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-11-14) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-21) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-22) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-02-29) - NEWINC