-
MINI CAMPERS NORTH EAST LIMITED - Unit 2 Browns Yard, Brunswick Industrial Estate, Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07953751
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 2 Browns Yard
- Brunswick Industrial Estate
- Newcastle Upon Tyne
- Tyne And Wear
- NE13 7BA
- United Kingdom Unit 2 Browns Yard, Brunswick Industrial Estate, Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear, NE13 7BA, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BANKS, Alex Gordon
- WILSON, Andrew
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.02.2012
- Alter der Firma 2012-02-17 12 Jahre
- SIC/NACE
- 45112
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Andrew Wilson
- Mr Andrew Wilson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- GATEWAY LEASING LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-01
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-10-26
- Letzte Einreichung: 2021-10-12
-
MINI CAMPERS NORTH EAST LIMITED Firmenbeschreibung
- MINI CAMPERS NORTH EAST LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07953751. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.02.2012 registriert. MINI CAMPERS NORTH EAST LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GATEWAY LEASING LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45112" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 01.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Unit 2 Browns Yard erreicht werden.
Jetzt sichern MINI CAMPERS NORTH EAST LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mini Campers North East Limited - Unit 2 Browns Yard, Brunswick Industrial Estate, Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear, Grossbritannien
- 2012-02-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MINI CAMPERS NORTH EAST LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-11-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-10-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-14) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-10-12) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-19) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-24) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-10) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-17) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-09-17) - PSC04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-17) - AP01
-
termination-director-company (2018-10-19) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-19) - TM01
-
resolution (2018-09-03) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-18) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-11-10) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-27) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-28) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-18) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-05-13) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-05) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-19) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-07-17) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-16) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-07) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-01-07) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-04) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-10-17) - AA01
-
capital-allotment-shares (2013-01-29) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-12) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-25) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-10-03) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-02-23) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-02-20) - TM01
-
incorporation-company (2012-02-17) - NEWINC