-
NEXMO LIMITED - C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor, London, E14 5HU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07935346
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place
- 10th Floor
- London
- E14 5HU
- United Kingdom C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor, London, E14 5HU, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- LEVI, David
- RUTHERFORD, Randy
- Prokuristen
- RUTHERFORD, Randy
- CORPORATION SERVICE COMPANY (UK) LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.02.2012
- Alter der Firma 2012-02-03 12 Jahre
- SIC/NACE
- 61900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Vonage Holdings Corp.
- Vonage Holdings Corp.
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-03
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-17
- Letzte Einreichung: 2021-02-03
-
NEXMO LIMITED Firmenbeschreibung
- NEXMO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07935346. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.02.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "61900" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 2 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 03.02.2013.Die Firma kann schriftlich über C/o Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place erreicht werden.
Jetzt sichern NEXMO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Nexmo Limited - C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor, London, E14 5HU, Grossbritannien
- 2012-02-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NEXMO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-04-29) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-02-15) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-12-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-15) - CS01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2021-10-21) - CH04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-10-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-18) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-08) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-14) - CS01
-
resolution (2019-02-15) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-08) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-07-24) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-10-09) - AA
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2019-07-24) - AP04
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-06) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-07) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-07) - CS01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-03-07) - PSC09
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-23) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-23) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-17) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-06-23) - AP03
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-22) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-08-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-01) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-02-17) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-02-16) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2016-01-12) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-18) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-08) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-09-18) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-01) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-03-01) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-02-03) - NEWINC