-
THE POINT AT POLZEATH PROPERTIES LIMITED - 1a Eddystone Road, Wadebridge, Cornwall, PL27 7AL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07926608
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1a Eddystone Road
- Wadebridge
- Cornwall
- PL27 7AL 1a Eddystone Road, Wadebridge, Cornwall, PL27 7AL UK
Management
- Geschäftsführung
- CLIVE, Robert David Tress
- DAVIES, Jeremy Jenkin
- KERSHAW, Michael George Aidan
- RODE DAVIES, Eva Eleonora
- O'DONNELL, Thomas Mark
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.01.2012
- Alter der Firma 2012-01-27 12 Jahre
- SIC/NACE
- 93110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Eva Eleonora Rode Davies
- Mr Jeremy Jenkin Davies
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ROSERROW 2012 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-10
- Letzte Einreichung: 2021-01-27
-
THE POINT AT POLZEATH PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- THE POINT AT POLZEATH PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07926608. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.01.2012 registriert. THE POINT AT POLZEATH PROPERTIES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ROSERROW 2012 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "93110" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 1A Eddystone Road erreicht werden.
Jetzt sichern THE POINT AT POLZEATH PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Point At Polzeath Properties Limited - 1a Eddystone Road, Wadebridge, Cornwall, PL27 7AL, Grossbritannien
- 2012-01-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE POINT AT POLZEATH PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-02) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-03-02) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-02) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-07-05) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-27) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-26) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-27) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-26) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-15) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-15) - PSC04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-14) - PSC04
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-04-22) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-02-03) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-25) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name (2014-01-31) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-14) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-10-24) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-09-06) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-03) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-04-02) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-24) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
certificate-change-of-name-company (2012-01-27) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-31) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-01-31) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-01) - AP01
-
resolution (2012-02-06) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2012-02-09) - SH02
-
certificate-change-of-name-company (2012-02-10) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-20) - AP01
-
capital-allotment-shares (2012-02-20) - SH01
-
resolution (2012-02-21) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2012-01-27) - NEWINC