-
URBAN CAR SPA LIMITED - Spa House, 18 Upper Grosvenor Road, Tunbridge Wells, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07917407
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Spa House
- 18 Upper Grosvenor Road
- Tunbridge Wells
- Kent
- TN1 2EP Spa House, 18 Upper Grosvenor Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 2EP UK
Management
- Geschäftsführung
- GRANT, Anthony Bryce
- REES-DAVIES, Jonathan Gerard
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.01.2012
- Gelöscht am:
- 2020-12-07
- SIC/NACE
- 81222
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Jonathan Gerard Rees-Davies
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-02-03
- Letzte Einreichung: 2019-01-20
-
URBAN CAR SPA LIMITED Firmenbeschreibung
- URBAN CAR SPA LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07917407. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 20.01.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "81222" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Spa House erreicht werden.
Jetzt sichern URBAN CAR SPA LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Urban Car Spa Limited - Spa House, 18 Upper Grosvenor Road, Tunbridge Wells, Kent, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu URBAN CAR SPA LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-09-07) - LIQ14
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2020-01-24) - DISS16(SOAS)
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-02-13) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-02-13) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-04-09) - AD01
-
resolution (2020-02-20) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-10) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-30) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-02-09) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-03-21) - SH01
-
gazette-notice-compulsory (2018-12-11) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-22) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-03) - CS01
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-01-24) - SH03
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-12-20) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-11-14) - AA01
-
resolution (2016-11-15) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-17) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-07) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-17) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-08-25) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-20) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-05) - AD01
-
resolution (2014-07-01) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2014-07-01) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-07-01) - SH02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-11) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-07-22) - SH01
-
resolution (2014-08-12) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-08-12) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-10) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-10-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-01-20) - NEWINC