-
FISHER CARE GROUP LIMITED - Henson House Planet Place, George Stephenson Industrial Estate, Newcastle Upon Tyne, NE12 6RZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07914544
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Henson House Planet Place
- George Stephenson Industrial Estate
- Newcastle Upon Tyne
- NE12 6RZ
- United Kingdom Henson House Planet Place, George Stephenson Industrial Estate, Newcastle Upon Tyne, NE12 6RZ, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- FISHER, Joshua John
- GILBERT, Simon Peter
- MORSE, John Bede
- MUSGRAVE, Paul Brian
- WILSON, David Nathan
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.01.2012
- Alter der Firma 2012-01-18 12 Jahre
- SIC/NACE
- 87100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Nathan Wilson
- Mr John Fisher
- Esk Hall Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- TFP - HENSON HEALTHCARE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-01
- Letzte Einreichung: 2020-01-18
-
FISHER CARE GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- FISHER CARE GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07914544. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.01.2012 registriert. FISHER CARE GROUP LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen TFP - HENSON HEALTHCARE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "87100" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Henson House Planet Place erreicht werden.
Jetzt sichern FISHER CARE GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fisher Care Group Limited - Henson House Planet Place, George Stephenson Industrial Estate, Newcastle Upon Tyne, NE12 6RZ, Grossbritannien
- 2012-01-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FISHER CARE GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-01-10) - PSC07
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-01-22) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-01-22) - PSC04
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-06-12) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-04-15) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-24) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-10-29) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-01) - PSC04
-
resolution (2018-10-23) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-09) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-05) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-05) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-05) - PSC01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-02-01) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2018-02-01) - CH03
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-25) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-20) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-20) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-27) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-11-18) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-20) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-02-20) - CH03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-18) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-28) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-01-28) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-03) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-02-28) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-01) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-10-17) - AP03
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-08-17) - AA01
-
incorporation-company (2012-01-18) - NEWINC