-
COURTLAND DENTAL CENTRE LIMITED - 15 Basset Court Loake Close, Grange Park, Northampton, NN4 5EZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07912981
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 15 Basset Court Loake Close
- Grange Park
- Northampton
- NN4 5EZ
- England 15 Basset Court Loake Close, Grange Park, Northampton, NN4 5EZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FARRELL, Dawn
- MEHRA, Shalin
- BRADY, Catherine Bernadette
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.01.2012
- Alter der Firma 2012-01-17 12 Jahre
- SIC/NACE
- 86230
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- United Dental Limited
- -
- Rodericks Dental Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-09-28
- Letzte Einreichung: 2023-09-14
-
COURTLAND DENTAL CENTRE LIMITED Firmenbeschreibung
- COURTLAND DENTAL CENTRE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07912981. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.01.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86230" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.01.2013.Die Firma kann schriftlich über 15 Basset Court Loake Close erreicht werden.
Jetzt sichern COURTLAND DENTAL CENTRE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Courtland Dental Centre Limited - 15 Basset Court Loake Close, Grange Park, Northampton, NN4 5EZ, Grossbritannien
- 2012-01-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu COURTLAND DENTAL CENTRE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
legacy (2023-01-19) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-01-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-19) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-09-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-17) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-04-27) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-10-25) - AP01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-10-25) - PSC05
-
legacy (2022-12-19) - GUARANTEE2
-
legacy (2022-12-19) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-12-01) - AA
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-03-26) - AA
-
legacy (2021-03-30) - GUARANTEE2
-
legacy (2021-11-22) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-20) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-09-17) - CH01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-20) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-06) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-06-06) - PSC05
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-06) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-28) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-06) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-08-07) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-31) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-16) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-05-29) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-29) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-13) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-04-09) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-23) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-12) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-14) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-08) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-01-31) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-01-17) - NEWINC