-
FIRSDIT LTD - 1 Vincent Square, London, SW1P 2PN, United Kingdom, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07892925
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Vincent Square
- London
- SW1P 2PN
- United Kingdom 1 Vincent Square, London, SW1P 2PN, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- DORRELL, Stephen James
- MEIER, Paul Stryker
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.12.2011
- Alter der Firma 2011-12-28 12 Jahre
- SIC/NACE
- 58142
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Public Policy Projects Limited
- Dorson Transform Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- VIVA HEALTHCARE PUBLISHING LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-28
- Letzte Einreichung: 2019-12-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-11
- Letzte Einreichung: 2020-12-28
-
FIRSDIT LTD Firmenbeschreibung
- FIRSDIT LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07892925. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.12.2011 registriert. FIRSDIT LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen VIVA HEALTHCARE PUBLISHING LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "58142" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 28.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 1 Vincent Square erreicht werden.
Jetzt sichern FIRSDIT LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Firsdit Ltd - 1 Vincent Square, London, SW1P 2PN, United Kingdom, Grossbritannien
- 2011-12-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FIRSDIT LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-05-14) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-14) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-05-14) - PSC05
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-05-15) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2021-04-13) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-20) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-28) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-12-23) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-09-30) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-31) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-13) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-18) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-28) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-18) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-02) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-14) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-11) - PSC02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-12-11) - PSC05
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-11) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-02) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
certificate-change-of-name-company (2016-03-15) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-26) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-03-02) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-22) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-19) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-09-30) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-19) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-19) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-20) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-12) - AP01
-
resolution (2012-01-17) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2012-01-17) - SH08
-
capital-alter-shares-subdivision (2012-01-17) - SH02
-
capital-allotment-shares (2012-01-17) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-08-14) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2012-06-28) - TM01
-
termination-director-company-with-name (2012-11-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-15) - AP01
-
legacy (2012-03-01) - MG01
-
certificate-change-of-name-company (2012-01-03) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-12-28) - NEWINC