-
SPARTENT GLOBAL SOLUTIONS LIMITED - 26 High Street, Haslemere, GU27 2HW, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07890792
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 26 High Street
- Haslemere
- GU27 2HW
- England 26 High Street, Haslemere, GU27 2HW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MURRIN, David Paul
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.12.2011
- Alter der Firma 2011-12-22 12 Jahre
- SIC/NACE
- 80100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Paul Murrin
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- EMERGENT RISK SOLUTIONS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-05
- Letzte Einreichung: 2020-12-22
-
SPARTENT GLOBAL SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- SPARTENT GLOBAL SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07890792. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.12.2011 registriert. SPARTENT GLOBAL SOLUTIONS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen EMERGENT RISK SOLUTIONS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "80100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 26 High Street erreicht werden.
Jetzt sichern SPARTENT GLOBAL SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Spartent Global Solutions Limited - 26 High Street, Haslemere, GU27 2HW, England, Grossbritannien
- 2011-12-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SPARTENT GLOBAL SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-30) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-04-16) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-13) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-04-12) - SH01
-
gazette-notice-compulsory (2019-03-12) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-notice-compulsory (2018-03-13) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-03) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-04-04) - DISS40
-
resolution (2018-05-08) - RESOLUTIONS
-
legacy (2018-05-08) - CAP-SS
-
capital-alter-shares-subdivision (2018-05-08) - SH02
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-05-08) - SH08
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2018-05-24) - SH19
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-31) - AA
-
legacy (2018-05-08) - SH20
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-12-21) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-07) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-24) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-23) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-19) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-17) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-27) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-20) - AA
-
capital-allotment-shares (2015-10-28) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-10-26) - SH02
-
capital-allotment-shares (2015-08-18) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-20) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-18) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-01-20) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-13) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-08) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-29) - MR01
-
resolution (2014-11-03) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2014-10-29) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-20) - AA
-
capital-allotment-shares (2013-05-16) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-02-15) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-02-11) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
certificate-change-of-name-company (2012-02-22) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2012-02-22) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-12-22) - NEWINC