-
AQH MICKLEGATE LIMITED - Oxford Chambers Oxford Road, Guiseley, Leeds, LS20 9AT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07889122
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Oxford Chambers Oxford Road
- Guiseley
- Leeds
- LS20 9AT Oxford Chambers Oxford Road, Guiseley, Leeds, LS20 9AT UK
Management
- Geschäftsführung
- JOYCE, Martin Andrew
- MURPHY, Stephen Bernard
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.12.2011
- Gelöscht am:
- 2020-11-11
- SIC/NACE
- 68100
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- GWECO 530 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-09-30
- Letzte Einreichung: 2014-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-21
-
AQH MICKLEGATE LIMITED Firmenbeschreibung
- AQH MICKLEGATE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07889122. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 21.12.2011 registriert. AQH MICKLEGATE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GWECO 530 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 21.12.2012.Die Firma kann schriftlich über Oxford Chambers Oxford Road erreicht werden.
Jetzt sichern AQH MICKLEGATE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Aqh Micklegate Limited - Oxford Chambers Oxford Road, Guiseley, Leeds, LS20 9AT, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AQH MICKLEGATE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-11-11) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2020-01-02) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-01-08) - 600
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2020-08-11) - LIQ13
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-05-13) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-05-03) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-08-30) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-05-25) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-20) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-02-25) - MR04
-
resolution (2016-03-16) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2016-03-16) - 4.70
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-03-16) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-17) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-03-10) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-05) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-06-25) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-23) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-13) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-02-20) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-03-05) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-04) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-03-03) - MR04
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-18) - AR01
-
legacy (2013-03-19) - MG02
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-04-08) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-05-22) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-25) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-08-28) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-11-23) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-09-05) - MR04
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-11-19) - MG02
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-10-24) - AA01
-
legacy (2012-09-03) - MG02
-
legacy (2012-03-31) - MG01
-
change-of-name-notice (2012-01-19) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2012-01-19) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name (2012-01-24) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-01-24) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-01-24) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-24) - AP01
-
capital-allotment-shares (2012-01-25) - SH01
-
legacy (2012-04-07) - MG01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-05-09) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-12-21) - NEWINC