-
HEALTH FACILITIES LIMITED - The Karri Clinic Suite 2 Albion Mills, Albion Lane, Willerby, East Riding, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07887004
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Karri Clinic Suite 2 Albion Mills
- Albion Lane
- Willerby
- East Riding
- HU10 6DN
- England The Karri Clinic Suite 2 Albion Mills, Albion Lane, Willerby, East Riding, HU10 6DN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- KARRI, Suzanne Helen
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.12.2011
- Alter der Firma 2011-12-20 12 Jahre
- SIC/NACE
- 86220
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Vasu Karri
- The Strandhill Group Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-07-31
- Letzte Einreichung: 2020-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-26
- Letzte Einreichung: 2021-01-12
-
HEALTH FACILITIES LIMITED Firmenbeschreibung
- HEALTH FACILITIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07887004. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.12.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86220" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.12.2012.Die Firma kann schriftlich über The Karri Clinic Suite 2 Albion Mills erreicht werden.
Jetzt sichern HEALTH FACILITIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Health Facilities Limited - The Karri Clinic Suite 2 Albion Mills, Albion Lane, Willerby, East Riding, Grossbritannien
- 2011-12-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HEALTH FACILITIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-06-24) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-01-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-25) - PSC07
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-24) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-24) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-26) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2018-02-27) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-02-28) - DISS40
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-03-26) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-26) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-05) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-16) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-12) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-12) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-01-12) - TM02
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-12-24) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-06) - AR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-19) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-01-19) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-18) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-of-name-notice (2013-01-21) - CONNOT
-
resolution (2013-01-21) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-23) - AP01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-01-23) - CH03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-01-24) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-08-27) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-08-30) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-20) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-11-01) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-01-24) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-12-20) - NEWINC