-
ROJA PARFUMS HOLDINGS LIMITED - 41 New England Street, New England Quarter, Brighton, BN1 4GQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07881919
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 41 New England Street
- New England Quarter
- Brighton
- BN1 4GQ 41 New England Street, New England Quarter, Brighton, BN1 4GQ UK
Management
- Geschäftsführung
- CAUSER, Peter John
- DOVE, Roger John
- KELLY, Jamie Robert
- VENTON, Dominic David
- MINARD, Audrey
- Prokuristen
- CAUSER, Peter
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.12.2011
- Alter der Firma 2011-12-14 12 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- -
- -
- Roja Parfums Holdings Ii Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-12-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-24
- Letzte Einreichung: 2020-10-10
-
ROJA PARFUMS HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- ROJA PARFUMS HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07881919. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.12.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.12.2014.Die Firma kann schriftlich über 41 New England Street erreicht werden.
Jetzt sichern ROJA PARFUMS HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Roja Parfums Holdings Limited - 41 New England Street, New England Quarter, Brighton, BN1 4GQ, Grossbritannien
- 2011-12-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ROJA PARFUMS HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-09-02) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2020-06-26) - SH19
-
confirmation-statement-with-updates (2020-11-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-20) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-06-29) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-06-29) - PSC07
-
legacy (2020-06-26) - SH20
-
legacy (2020-06-26) - CAP-SS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-06-25) - PSC02
-
resolution (2020-06-26) - RESOLUTIONS
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-06-25) - PSC07
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-06-19) - MR04
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2020-03-16) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-03-16) - SH08
-
resolution (2020-03-13) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-02-12) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-02-11) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2019-02-25) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-01) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-02-25) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-07) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-02-25) - PSC07
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-11) - PSC07
-
resolution (2019-04-26) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-12-18) - AA
-
capital-allotment-shares (2018-06-11) - SH01
-
capital-return-purchase-own-shares (2018-06-11) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2018-06-11) - SH06
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-21) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-21) - PSC01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-11-08) - CH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-12-21) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-23) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-08-15) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-08-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-28) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-08-28) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-21) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-01-18) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-12-14) - NEWINC