-
GRIMSBY DEMENTIA CARE LTD - The Val Waterhouse Centre, 41-43 Kent Street, Grimsby, North East Lincolnshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07878472
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Val Waterhouse Centre
- 41-43 Kent Street
- Grimsby
- North East Lincolnshire
- DN32 7DH The Val Waterhouse Centre, 41-43 Kent Street, Grimsby, North East Lincolnshire, DN32 7DH UK
Management
- Geschäftsführung
- MILLER, Jane
- REVELL, Lisa Gale
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.12.2011
- Alter der Firma 2011-12-12 12 Jahre
- SIC/NACE
- 87300
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mrs Kerry Campling
- Mrs Jane Miller
- Mrs Lisa Gale Revell
- -
- Mrs Jane Miller
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-30
- Letzte Einreichung: 2021-03-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-26
- Letzte Einreichung: 2020-12-12
-
GRIMSBY DEMENTIA CARE LTD Firmenbeschreibung
- GRIMSBY DEMENTIA CARE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07878472. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.12.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "87300" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über The Val Waterhouse Centre erreicht werden.
Jetzt sichern GRIMSBY DEMENTIA CARE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Grimsby Dementia Care Ltd - The Val Waterhouse Centre, 41-43 Kent Street, Grimsby, North East Lincolnshire, Grossbritannien
- 2011-12-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GRIMSBY DEMENTIA CARE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-09-21) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-01-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-24) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-02-26) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-08-28) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-27) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-12-16) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-16) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-03-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-19) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-21) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-25) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-12) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-08) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-12-12) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-21) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-12-21) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-21) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-21) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-06-01) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-06-04) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-19) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-04-15) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-05) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-01-05) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-01-08) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-09) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-08-06) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-09) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-02-09) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-02-09) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-02-29) - MG01
-
legacy (2012-02-22) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-12-12) - NEWINC