-
ALTARAS INTERNATIONAL WORCESTER LIMITED - Morvern House Ormonde Drive, Denby, Ripley, DE5 8LE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07877065
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Morvern House Ormonde Drive
- Denby
- Ripley
- DE5 8LE
- England Morvern House Ormonde Drive, Denby, Ripley, DE5 8LE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FREIMUND, Jorg Helmut
- LEWIS, Phillip Andrew, Dr
- SIMPSON, Ian
- STEEN, Jason
- STEFFENS, Klaus
- Prokuristen
- MCGREEVY, Paul
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.12.2011
- Alter der Firma 2011-12-09 12 Jahre
- SIC/NACE
- 28990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- DELTACAM INTERNATIONAL LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-09
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-12-23
- Letzte Einreichung: 2023-12-09
-
ALTARAS INTERNATIONAL WORCESTER LIMITED Firmenbeschreibung
- ALTARAS INTERNATIONAL WORCESTER LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07877065. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.12.2011 registriert. ALTARAS INTERNATIONAL WORCESTER LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DELTACAM INTERNATIONAL LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "28990" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.12.2012.Die Firma kann schriftlich über Morvern House Ormonde Drive erreicht werden.
Jetzt sichern ALTARAS INTERNATIONAL WORCESTER LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Altaras International Worcester Limited - Morvern House Ormonde Drive, Denby, Ripley, DE5 8LE, Grossbritannien
- 2011-12-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ALTARAS INTERNATIONAL WORCESTER LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-02-07) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2024-01-04) - CH01
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-09-24) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-03-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-03-15) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-01-13) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-12-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-12-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-09-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-12-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-18) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-26) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-01-24) - MR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-06-26) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-12) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-26) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-09-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-18) - CS01
-
resolution (2019-01-29) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-20) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-11-21) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-06-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-17) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-21) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-14) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-14) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-12) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-16) - CS01
-
resolution (2017-01-25) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-21) - AA
-
memorandum-articles (2017-01-25) - MA
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-12-22) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-21) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-26) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
certificate-change-of-name-company (2013-04-10) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2013-04-10) - CONNOT
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-07-10) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-11) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-31) - AR01
-
capital-allotment-shares (2012-09-10) - SH01
-
resolution (2012-09-10) - RESOLUTIONS
-
resolution (2012-08-08) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2012-08-08) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2012-08-08) - SH08
-
legacy (2012-06-15) - MG01
-
termination-director-company-with-name (2012-02-27) - TM01
-
capital-allotment-shares (2012-02-24) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-24) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-12-09) - NEWINC