-
RECHEM LTD - Atlas House Third Avenue, Globe Park, Marlow, Buckinghamshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07869616
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Atlas House Third Avenue
- Globe Park
- Marlow
- Buckinghamshire
- SL7 1EY
- England Atlas House Third Avenue, Globe Park, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1EY, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CREIXELL DE VILLALONGA, Victor
- GRUPO TRADEBE MEDIOAMBIENTE SL
- SEGARRA, Oriol
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.12.2011
- Alter der Firma 2011-12-02 12 Jahre
- SIC/NACE
- 38220
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Hollywell Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2018-04-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-01
- Letzte Einreichung: 2023-04-17
-
RECHEM LTD Firmenbeschreibung
- RECHEM LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07869616. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.12.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "38220" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.04.2018.Die Firma kann schriftlich über Atlas House Third Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern RECHEM LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rechem Ltd - Atlas House Third Avenue, Globe Park, Marlow, Buckinghamshire, Grossbritannien
- 2011-12-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RECHEM LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-04-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-08-14) - AA
-
legacy (2023-08-14) - PARENT_ACC
-
legacy (2023-08-14) - AGREEMENT2
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-05-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-05-09) - TM01
-
legacy (2023-08-14) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-29) - CS01
-
legacy (2022-12-20) - AGREEMENT2
-
legacy (2022-12-20) - GUARANTEE2
-
legacy (2022-12-20) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2022-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-04-06) - AP01
-
change-corporate-director-company-with-change-date (2021-03-23) - CH02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-04-06) - TM01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-04-28) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-09-02) - AA
-
legacy (2021-09-02) - PARENT_ACC
-
legacy (2021-09-02) - AGREEMENT2
-
legacy (2021-09-02) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-07-23) - AA
-
legacy (2020-07-23) - PARENT_ACC
-
legacy (2020-07-23) - AGREEMENT2
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-31) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-27) - CS01
-
legacy (2020-07-23) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2019
-
legacy (2019-10-21) - AGREEMENT2
-
legacy (2019-10-21) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-21) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-09) - AA
-
legacy (2019-10-21) - PARENT_ACC
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-01-11) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-12) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-18) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-17) - AP01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2018-01-11) - AP02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-05) - TM01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2018-11-05) - AP02
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-05-03) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-11) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-12) - CS01
-
capital-allotment-shares (2016-12-12) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-15) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-16) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
dissolution-withdrawal-application-strike-off-company (2013-11-29) - DS02
-
gazette-notice-voluntary (2013-11-05) - GAZ1(A)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-16) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-03-18) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-22) - AR01
-
dissolution-application-strike-off-company (2013-10-22) - DS01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-12-02) - NEWINC