-
GREENER GLAZING HOME IMPROVEMENTS LIMITED - Beauchamp House 402-403 Stourport Road, Stourport Road, Kidderminster, Worcestershire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07850800
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Beauchamp House 402-403 Stourport Road
- Stourport Road
- Kidderminster
- Worcestershire
- DY11 7BG
- England Beauchamp House 402-403 Stourport Road, Stourport Road, Kidderminster, Worcestershire, DY11 7BG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.11.2011
- Alter der Firma 2011-11-17 12 Jahre
- SIC/NACE
- 43342
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Glen Adam Darby
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-08-31
- Letzte Einreichung: 2022-11-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-12-01
- Letzte Einreichung: 2022-11-17
-
GREENER GLAZING HOME IMPROVEMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- GREENER GLAZING HOME IMPROVEMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07850800. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.11.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43342" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2022 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.11.2012.Die Firma kann schriftlich über Beauchamp House 402-403 Stourport Road erreicht werden.
Jetzt sichern GREENER GLAZING HOME IMPROVEMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Greener Glazing Home Improvements Limited - Beauchamp House 402-403 Stourport Road, Stourport Road, Kidderminster, Worcestershire, Grossbritannien
- 2011-11-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GREENER GLAZING HOME IMPROVEMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-08-30) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-10-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-12-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-21) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-01-28) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-01-26) - CS01
-
capital-allotment-shares (2021-01-25) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-26) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-25) - CS01
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-10-29) - SH08
-
resolution (2019-10-29) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-23) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-26) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-21) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-27) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-05-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-14) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-10) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-09) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-28) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-01) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-10-01) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-17) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-11-17) - NEWINC