-
COMPASS VEHICLE SOLUTIONS LTD - Foundry Garage Rear Of Noel Village Estate, Carr Hill, Doncaster, South Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07848806
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Foundry Garage Rear Of Noel Village Estate
- Carr Hill
- Doncaster
- South Yorkshire
- DN4 8DE
- United Kingdom Foundry Garage Rear Of Noel Village Estate, Carr Hill, Doncaster, South Yorkshire, DN4 8DE, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- JENNISON, Kevin Roger
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.11.2011
- Alter der Firma 2011-11-16 12 Jahre
- SIC/NACE
- 45200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Sonia Prescott
- Mr Richard Tagg
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-08-31
- Letzte Einreichung: 2020-11-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-16
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-11-30
- Letzte Einreichung: 2021-11-16
-
COMPASS VEHICLE SOLUTIONS LTD Firmenbeschreibung
- COMPASS VEHICLE SOLUTIONS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07848806. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.11.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45200" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.11.2012.Die Firma kann schriftlich über Foundry Garage Rear Of Noel Village Estate erreicht werden.
Jetzt sichern COMPASS VEHICLE SOLUTIONS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Compass Vehicle Solutions Ltd - Foundry Garage Rear Of Noel Village Estate, Carr Hill, Doncaster, South Yorkshire, Grossbritannien
- 2011-11-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu COMPASS VEHICLE SOLUTIONS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-29) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-10) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-11-25) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-11-25) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-26) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-23) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-23) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-23) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-10-31) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2018-10-30) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-24) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-03-12) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-12) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-08-22) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-06-12) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-04-23) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-02-13) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-12) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-28) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-13) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-08-28) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-29) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-28) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-22) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-23) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-10-31) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-10) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-08-23) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-08-23) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-11-16) - NEWINC