-
MARK SCOTT SALONS LIMITED - 109 Swan Street, Sileby, LE12 7NN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07842787
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 109 Swan Street
- Sileby
- LE12 7NN 109 Swan Street, Sileby, LE12 7NN UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.11.2011
- Gelöscht am:
- 2022-10-27
- SIC/NACE
- 96020
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Mark Scott Theaker
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- MARK SCOTT (LONDON ROAD) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-07-29
- Letzte Einreichung: 2017-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-11-24
- Letzte Einreichung: 2017-11-10
-
MARK SCOTT SALONS LIMITED Firmenbeschreibung
- MARK SCOTT SALONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07842787. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 10.11.2011 registriert. MARK SCOTT SALONS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MARK SCOTT (LONDON ROAD) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96020" registriert. Die Firma kann schriftlich über 109 Swan Street erreicht werden.
Jetzt sichern MARK SCOTT SALONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mark Scott Salons Limited - 109 Swan Street, Sileby, LE12 7NN, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MARK SCOTT SALONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-03-23) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-04-21) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-05) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-03-02) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-03-02) - LIQ02
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-02-23) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2019-02-05) - GAZ1
-
resolution (2019-04-15) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-10-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-07-29) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-02) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-02) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-06) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2017-02-07) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-02-08) - DISS40
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-07-28) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-23) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-27) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-23) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-11-19) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-07-28) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-07-29) - AA01
-
certificate-change-of-name-company (2015-02-26) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-25) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-25) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-27) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-11) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-11) - AP01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-03-12) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2014-03-11) - GAZ1
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-13) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-29) - AA
-
termination-director-company-with-name (2014-06-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-18) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-07-19) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-04-25) - TM01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-03-23) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-20) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-03-19) - AD01
-
gazette-notice-compulsary (2013-03-12) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-11-10) - NEWINC