-
AIRFLOW COOLING LTD - Charlotte House, 500 Charlotte Road, Sheffield, South Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07842523
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Charlotte House
- 500 Charlotte Road
- Sheffield
- South Yorkshire
- S2 4ER
- England Charlotte House, 500 Charlotte Road, Sheffield, South Yorkshire, S2 4ER, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DENTON, Mark
- PIERCEY, Daniel Kyle
- STANIFORTH, Thomas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.11.2011
- Alter der Firma 2011-11-10 12 Jahre
- SIC/NACE
- 43220
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- -
- Airflow Cooling Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-10
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-03
- Letzte Einreichung: 2019-11-22
-
AIRFLOW COOLING LTD Firmenbeschreibung
- AIRFLOW COOLING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07842523. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.11.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43220" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 10.11.2012.Die Firma kann schriftlich über Charlotte House erreicht werden.
Jetzt sichern AIRFLOW COOLING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Airflow Cooling Ltd - Charlotte House, 500 Charlotte Road, Sheffield, South Yorkshire, Grossbritannien
- 2011-11-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AIRFLOW COOLING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-27) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-10) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-27) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-11-26) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-18) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-11-27) - PSC05
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-08) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-01-08) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-08) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-01-17) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-22) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-17) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-10-19) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-03) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-02) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-06-05) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-10) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-15) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-05-19) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-11) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-19) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-13) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-13) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-01) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-14) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-30) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-21) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-06-10) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-06-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-10) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-10) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-11-14) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-14) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-11-26) - CH01
-
termination-director-company-with-name (2013-06-10) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-allotment-shares (2012-12-20) - SH01
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-11-25) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-11-22) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-11-11) - TM01
-
incorporation-company (2011-11-10) - NEWINC