-
MAILSERVE LTD - Bevan Kidwell Llp, 113-117 Farringdon Road, London, EC1R 3BX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07837195
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Bevan Kidwell Llp
- 113-117 Farringdon Road
- London
- EC1R 3BX
- England Bevan Kidwell Llp, 113-117 Farringdon Road, London, EC1R 3BX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BEVAN, George William
- BEVAN, Helen
- SMITH, Mark
- TAYLOR, Ged
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.11.2011
- Alter der Firma 2011-11-07 12 Jahre
- SIC/NACE
- 77330
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- The Mailing Room Holdings Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-04-30
- Letzte Einreichung: 2020-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-11-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-11-21
- Letzte Einreichung: 2021-11-07
-
MAILSERVE LTD Firmenbeschreibung
- MAILSERVE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07837195. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.11.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "77330" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2013 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.11.2013.Die Firma kann schriftlich über Bevan Kidwell Llp erreicht werden.
Jetzt sichern MAILSERVE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mailserve Ltd - Bevan Kidwell Llp, 113-117 Farringdon Road, London, EC1R 3BX, Grossbritannien
- 2011-11-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MAILSERVE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-08-19) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-02-25) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-12) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
memorandum-articles (2019-12-24) - MA
-
resolution (2019-12-24) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-12-23) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-12-18) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-11-12) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-07) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-04-29) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-23) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-03-26) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-26) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-28) - PSC02
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-04-23) - SH08
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-03) - PSC07
-
resolution (2018-04-12) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-21) - AA
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2018-04-23) - SH10
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2018-04-30) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-18) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-08-09) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-08-08) - PSC04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-08) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-06-09) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-06) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-01-13) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-10-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-07) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-07) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-06-17) - AP01
-
capital-allotment-shares (2013-09-11) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-13) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-11-13) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-21) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-09-04) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-11-07) - NEWINC