-
SDL REALISATIONS 2020 LIMITED - Four Brindley Place, Brindley Place, Birmingham, B1 2HZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07827872
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Four Brindley Place
- Brindley Place
- Birmingham
- B1 2HZ Four Brindley Place, Brindley Place, Birmingham, B1 2HZ UK
Management
- Geschäftsführung
- MOHAMMED, Mustafa Tariq
- MUSTAFA, Safia
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.10.2011
- Alter der Firma 2011-10-28 12 Jahre
- SIC/NACE
- 86230
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Mustafa Tariq Mohammed
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- SPARKLE DENTAL LABS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-22
- Letzte Einreichung: 2019-12-11
-
SDL REALISATIONS 2020 LIMITED Firmenbeschreibung
- SDL REALISATIONS 2020 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07827872. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.10.2011 registriert. SDL REALISATIONS 2020 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SPARKLE DENTAL LABS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86230" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Four Brindley Place erreicht werden.
Jetzt sichern SDL REALISATIONS 2020 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sdl Realisations 2020 Limited - Four Brindley Place, Brindley Place, Birmingham, B1 2HZ, Grossbritannien
- 2011-10-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SDL REALISATIONS 2020 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
resolution (2021-02-27) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2021-02-27) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-11-10) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-28) - AA
-
resolution (2020-12-07) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-12-07) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-12-07) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-03-28) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-02-11) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-09) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2017-03-07) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-29) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-03-11) - DISS40
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-22) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-02) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-04-28) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-30) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-11-18) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-03) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-04) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-01-23) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-10-06) - MG01
-
termination-director-company-with-name (2012-07-20) - TM01
-
legacy (2012-07-20) - MG01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-06-07) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-13) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-11-29) - CH01
-
incorporation-company (2011-10-28) - NEWINC