-
COACH1 LIMITED - Jh Coaches Fell Bank, Birtley, Chester Le Street, County Durham, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07823015
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Jh Coaches Fell Bank
- Birtley
- Chester Le Street
- County Durham
- DH3 2SP Jh Coaches Fell Bank, Birtley, Chester Le Street, County Durham, DH3 2SP UK
Management
- Geschäftsführung
- SHIPLEY, Ian Raymond
- SHIPLEY, John Christopher
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.10.2011
- Alter der Firma 2011-10-25 12 Jahre
- SIC/NACE
- 49319
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr John Christopher Shipley
- John Matthew Fickling
- Ian Raymond Shipley
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-25
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-11-08
- Letzte Einreichung: 2023-10-25
-
COACH1 LIMITED Firmenbeschreibung
- COACH1 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07823015. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.10.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "49319" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 25.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Jh Coaches Fell Bank erreicht werden.
Jetzt sichern COACH1 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Coach1 Limited - Jh Coaches Fell Bank, Birtley, Chester Le Street, County Durham, Grossbritannien
- 2011-10-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu COACH1 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-11-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-12-22) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-11-21) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-11-23) - PSC01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-09-07) - MR04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-11-20) - PSC01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-10-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-10-26) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-05) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-07-07) - PSC04
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-23) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-12-23) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-12-23) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-02) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-04) - AR01
-
resolution (2015-01-20) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-28) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-01-20) - SH08
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-12) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-08-30) - MR01
-
capital-allotment-shares (2014-10-27) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-28) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-28) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-09-06) - MR04
-
capital-allotment-shares (2014-11-03) - SH01
-
capital-allotment-shares (2014-11-17) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-29) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-07-08) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-20) - AR01
-
resolution (2012-02-09) - RESOLUTIONS
-
legacy (2012-02-07) - MG01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-01-19) - AD01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-10-25) - NEWINC