-
QBITUS PRODUCTS LIMITED - Unit 8 Withey Court Western Industrial Estate, Caerphilly, Mid Glamorgan, Wales, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07815953
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 8 Withey Court Western Industrial Estate
- Caerphilly
- Mid Glamorgan
- Wales
- CF83 1BF
- United Kingdom Unit 8 Withey Court Western Industrial Estate, Caerphilly, Mid Glamorgan, Wales, CF83 1BF, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BOYLE, Gerard Joseph
- BRODIE, Robert Benjamin Nathaniel
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.10.2011
- Alter der Firma 2011-10-19 12 Jahre
- SIC/NACE
- 32990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Dhg Bidco Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-29
- Letzte Einreichung: 2020-02-15
-
QBITUS PRODUCTS LIMITED Firmenbeschreibung
- QBITUS PRODUCTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07815953. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.10.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "32990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 8 Withey Court Western Industrial Estate erreicht werden.
Jetzt sichern QBITUS PRODUCTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Qbitus Products Limited - Unit 8 Withey Court Western Industrial Estate, Caerphilly, Mid Glamorgan, Wales, Grossbritannien
- 2011-10-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu QBITUS PRODUCTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-10-02) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-27) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-04-09) - AP01
-
resolution (2020-10-01) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2020-09-18) - MA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-05-11) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-09) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-05-11) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-11-17) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2020-11-25) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-12-11) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-11-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-24) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-05-15) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-05-16) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-05-23) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-23) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-23) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-24) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-05-23) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-06-23) - MR04
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-07-05) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-20) - AA
-
change-account-reference-date-company (2018-09-12) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-22) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-01-17) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-07) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-08-26) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-10-21) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-21) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-21) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-10-21) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-21) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-26) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-03) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-23) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-05-21) - AA01
-
legacy (2012-02-18) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-10-19) - NEWINC