-
AUXERRE LIMITED - 10 London Mews, London, W2 1HY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07805314
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 10 London Mews
- London
- W2 1HY 10 London Mews, London, W2 1HY UK
Management
- Geschäftsführung
- AWAR, Rana
- TABIAT, Rachad
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.10.2011
- Alter der Firma 2011-10-11 12 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs May Jammal
- Mrs Rana Awar
- House 24 (London) Ltd
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-11
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-25
- Letzte Einreichung: 2020-10-11
-
AUXERRE LIMITED Firmenbeschreibung
- AUXERRE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07805314. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.10.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 10 London Mews erreicht werden.
Jetzt sichern AUXERRE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Auxerre Limited - 10 London Mews, London, W2 1HY, Grossbritannien
- 2011-10-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AUXERRE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-08) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-03-09) - DISS40
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-05-07) - MR04
-
gazette-notice-compulsory (2021-01-26) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-02) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-03-02) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-20) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-02) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-10-23) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-10-21) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-11) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-02-19) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-26) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-26) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-04) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-21) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-12) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-19) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-01) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-07-01) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-11) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-05-02) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-03-13) - AP01
-
resolution (2012-05-11) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2012-05-11) - MEM/ARTS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-05-24) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-10-22) - TM02
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-10-29) - CH01
-
capital-allotment-shares (2012-03-12) - SH01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-10-30) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-30) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-03-12) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-10-11) - NEWINC