-
FADE OUT LIMITED - Newbury House Aintree Avenue, White Horse Business Park, Trowbridge, Wiltshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07804572
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Newbury House Aintree Avenue
- White Horse Business Park
- Trowbridge
- Wiltshire
- BA14 0XB Newbury House Aintree Avenue, White Horse Business Park, Trowbridge, Wiltshire, BA14 0XB UK
Management
- Geschäftsführung
- LYNCH-STAUNTON, Graham Murray
- LYNCH-STAUNTON, Susan Angela
- PERCY, Geoffrey Michael
- Prokuristen
- HILL, Layla Rebecca
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.10.2011
- Alter der Firma 2011-10-10 12 Jahre
- SIC/NACE
- 46450
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Vivalis Group Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-24
- Letzte Einreichung: 2023-10-10
-
FADE OUT LIMITED Firmenbeschreibung
- FADE OUT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07804572. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.10.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46450" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Newbury House Aintree Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern FADE OUT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fade Out Limited - Newbury House Aintree Avenue, White Horse Business Park, Trowbridge, Wiltshire, Grossbritannien
- 2011-10-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FADE OUT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2024-01-10) - PSC07
keyboard_arrow_right 2023
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-08-30) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2023-10-10) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-12-04) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-11-16) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-10-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-10-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-20) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-07-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-01) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-04-15) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-10) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-10) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-09-18) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-09-18) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-01) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-07-22) - AP03
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-10-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-15) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-20) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-16) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-21) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-10-21) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-02-04) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-21) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-06) - TM01
-
termination-director-company (2015-10-22) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-11-20) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-11-11) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-07-15) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-07) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-11-05) - AA01
-
legacy (2012-07-24) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-10-10) - NEWINC