-
KIDDYUM LIMITED - C/O JT MAXWELL LIMITED, 169 Union Street, Oldham, OL1 1TD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07799081
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O JT MAXWELL LIMITED
- 169 Union Street
- Oldham
- OL1 1TD
- United Kingdom C/O JT MAXWELL LIMITED, 169 Union Street, Oldham, OL1 1TD, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- HYNES, Andrew Dennis
- HYNES, Jayne Claire
- QUINN, Richard
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.10.2011
- Alter der Firma 2011-10-05 12 Jahre
- SIC/NACE
- 10850
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ms Jayne Claire Hynes
- Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-10-31
- Letzte Einreichung: 2018-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-10-05
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-19
- Letzte Einreichung: 2020-10-05
-
KIDDYUM LIMITED Firmenbeschreibung
- KIDDYUM LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07799081. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.10.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "10850" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2018 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 05.10.2014.Die Firma kann schriftlich über C/o Jt Maxwell Limited erreicht werden.
Jetzt sichern KIDDYUM LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Kiddyum Limited - C/O JT MAXWELL LIMITED, 169 Union Street, Oldham, OL1 1TD, Grossbritannien
- 2011-10-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KIDDYUM LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-10-20) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-10-20) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-02-12) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-01) - CS01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-10-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-22) - TM01
-
resolution (2020-09-01) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-09-04) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-09-04) - LIQ02
keyboard_arrow_right 2019
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-05-08) - SH08
-
capital-allotment-shares (2019-05-08) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-29) - PSC02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-04-29) - PSC04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-04-01) - MR04
-
capital-allotment-shares (2019-03-27) - SH01
-
resolution (2019-05-09) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-13) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-22) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-12) - AP01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2019-07-30) - SH10
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-09-23) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-26) - AA
-
capital-allotment-shares (2018-05-24) - SH01
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-09-06) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-05-25) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-09-08) - SH01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-19) - CS01
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-09-28) - SH02
-
resolution (2016-09-26) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2016-09-28) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-16) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-09) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-16) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-06) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-07) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-14) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-08-14) - AP01
-
capital-allotment-shares (2013-08-09) - SH01
-
resolution (2013-08-09) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-30) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-11) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-05-20) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-05-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-10-05) - NEWINC