-
VECTOS (NORTH) LIMITED - Oxford Place, 61 Oxford Street, Manchester, M1 6EQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07794057
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Oxford Place
- 61 Oxford Street
- Manchester
- M1 6EQ
- England Oxford Place, 61 Oxford Street, Manchester, M1 6EQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- EDWARDS, Alan Jonathan, Doctor
- HARGREAVES, Christopher Robert
- PENHALL, Neil Christopher
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.10.2011
- Alter der Firma 2011-10-03 12 Jahre
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Slr Bd Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-03
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-10-17
- Letzte Einreichung: 2022-10-03
-
VECTOS (NORTH) LIMITED Firmenbeschreibung
- VECTOS (NORTH) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07794057. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.10.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 03.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Oxford Place erreicht werden.
Jetzt sichern VECTOS (NORTH) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Vectos (North) Limited - Oxford Place, 61 Oxford Street, Manchester, M1 6EQ, Grossbritannien
- 2011-10-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VECTOS (NORTH) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-02-14) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-02-28) - MR01
keyboard_arrow_right 2022
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-01-11) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-10-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-03-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-11) - TM01
-
memorandum-articles (2021-05-05) - MA
-
resolution (2021-05-05) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-04-23) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-04-12) - PSC07
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-10-07) - MR04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-04-12) - PSC02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-15) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-10-15) - CH01
-
capital-allotment-shares (2020-08-11) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-18) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-07) - AA
-
capital-allotment-shares (2018-10-09) - SH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-12-19) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-10) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-10-10) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-10-10) - PSC09
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-06) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-28) - AP01
-
capital-allotment-shares (2017-05-09) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-11) - AD01
-
resolution (2017-02-11) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2017-02-09) - SH02
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-02-09) - SH08
-
capital-allotment-shares (2017-02-09) - SH01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-06) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-01-13) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-10) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-05) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-02-09) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-11-24) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2011-10-07) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-10-07) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-10-07) - AP01
-
incorporation-company (2011-10-03) - NEWINC