-
CAVENDISH GREEN LIMITED - Ground Floor, Egerton House, 68 Baker Street, Weybridge, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07789982
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Ground Floor, Egerton House
- 68 Baker Street
- Weybridge
- Surrey
- KT13 8AL
- United Kingdom Ground Floor, Egerton House, 68 Baker Street, Weybridge, Surrey, KT13 8AL, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- EDWARDS, Timothy David
- JOHNS, Darren Matthew
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.09.2011
- Alter der Firma 2011-09-28 12 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Timothy David Edwards
- Mr Darren Matthew Johns
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-07-31
- Letzte Einreichung: 2020-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-10-12
- Letzte Einreichung: 2021-09-28
-
CAVENDISH GREEN LIMITED Firmenbeschreibung
- CAVENDISH GREEN LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07789982. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.09.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 28.09.2012.Die Firma kann schriftlich über Ground Floor, Egerton House erreicht werden.
Jetzt sichern CAVENDISH GREEN LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cavendish Green Limited - Ground Floor, Egerton House, 68 Baker Street, Weybridge, Surrey, Grossbritannien
- 2011-09-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CAVENDISH GREEN LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-28) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-25) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2020-06-30) - AA01
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-09-04) - SH08
-
resolution (2020-09-05) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-07) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-08-23) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-08-23) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-08-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-25) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-06-27) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-29) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-08-31) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-04) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-30) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-15) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-01) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-29) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-05) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2013-05-17) - TM02
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-09-28) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-10-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-10-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-10-10) - AP01