-
MELTOG LTD - Unit B, Copley Hill Trading Estate, Whitehall Road, Leeds, LS12 1HE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07768846
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit B
- Copley Hill Trading Estate, Whitehall Road
- Leeds
- LS12 1HE Unit B, Copley Hill Trading Estate, Whitehall Road, Leeds, LS12 1HE UK
Management
- Geschäftsführung
- GLOVER, Paul Stephen
- HEYWORTH, Julian Nicholas
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.09.2011
- Alter der Firma 2011-09-09 13 Jahre
- SIC/NACE
- 28290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Julian Nicholas Heyworth
- Mr Paul Stephen Glover
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- MODULAR DESTRUCTION SYSTEMS LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-02-28
- Letzte Einreichung: 2023-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-09
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-19
- Letzte Einreichung: 2023-08-05
-
MELTOG LTD Firmenbeschreibung
- MELTOG LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07768846. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.09.2011 registriert. MELTOG LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MODULAR DESTRUCTION SYSTEMS LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "28290" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.09.2012.Die Firma kann schriftlich über Unit B erreicht werden.
Jetzt sichern MELTOG LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Meltog Ltd - Unit B, Copley Hill Trading Estate, Whitehall Road, Leeds, LS12 1HE, Grossbritannien
- 2011-09-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MELTOG LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-02-29) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-02-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-08-09) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2023-10-31) - TM02
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-02-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2021-03-22) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-20) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-10) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-12-03) - RESOLUTIONS
-
capital-cancellation-shares (2018-12-03) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2018-12-03) - SH03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-11) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-01) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-03-16) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-02-09) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-04) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-cancellation-shares (2015-07-30) - SH06
-
capital-allotment-shares (2015-12-21) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-10) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-18) - TM01
-
capital-return-purchase-own-shares (2015-07-30) - SH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-19) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2015-06-18) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-08) - AA
-
termination-director-company-with-name (2014-01-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-23) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-07-19) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-07-19) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2012-07-19) - TM02
-
capital-allotment-shares (2012-06-18) - SH01
-
resolution (2012-06-18) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-09-09) - NEWINC